Familienbuch Drei Gleichen / Herrmann Genealogie

Genealogie (nicht nur) im Gothaer Land

Lesezeichen hinzufügen
BRODT, Edwin John

BRODT, Edwin John

männlich 1899 - 1951  (52 Jahre)


Angaben zur Person    |    Quellen    |    Ereignis-Karte    |    Alles

  • Name BRODT, Edwin John  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
    Geburt 30 Nov 1899  Utica, Oneida County, New York, USA Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort  [1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36
    Geschlecht männlich 
    Aufenthaltsort Sanford, York County, Maine, USA Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort  [15
    Aufenthaltsort 1900  Utica, Oneida County, New York, USA Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort (Alter 0 Jahre)   [16
    Marital Status: Single; Relation to Head: Son 
    Aufenthaltsort 1910  Utica, Oneida County, New York, USA Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort (Alter 10 Jahre)   [36
    Marital Status: Single; Relation to Head of House: Son 
    Aufenthaltsort 1 Jun 1915  Utica, Oneida County, New York, USA Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort (Alter 15 Jahre)   [5
    Relation to Head of House: Son 
    Aufenthaltsort 1917  Allegany County, New York, USA Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort (Alter 17 Jahre)   [13
    Aufenthaltsort 1920  Utica, Oneida County, New York, USA Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort (Alter 20 Jahre)   [4
    Relation to Head: Son; Residence Marital Status: Single 
    Aufenthaltsort 1925  Burrillville, Providence County, Rhode Island, USA Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort (Alter 25 Jahre)   [9
    Relation to Head of House: Head 
    Aufenthaltsort 1930  Smithfield, Providence County, Rhode Island, USA Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort (Alter 30 Jahre)   [2
    Marital Status: Married; Relation to Head: Head 
    Aufenthaltsort 1934  Providence County, Rhode Island, USA Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort (Alter 34 Jahre)   [17
    Aufenthaltsort 1940  Sanford, York County, Maine, USA Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort (Alter 40 Jahre)   [15
    Marital Status: Divorced; Relation to Head: Head 
    Tod 2 Dez 1951  [1, 3, 28
    Beerdigung North Smithfield, Providence County, Rhode Island, USA Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort  [1, 3, 28
    Geschwister 2 Brüder und 2 Schwestern 
    Personen-Kennung I35949  Herrmann
    Zuletzt bearbeitet am 19 Feb 2026 

    Vater BRODT, Ernst
              geb. 6 Jun 1872, Deutschland Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort
              gest. 9 Sep 1944, Utica, Oneida County, New York, USA Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort (Alter 72 Jahre) 
    Mutter Lebend 
    Familien-Kennung F11556  Familienblatt  |  Familientafel

    Familie HARTZ, Lillian M
              geb. um 1903, New York, USA Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort
              gest. Datum unbekannt 
    Eheschließung 16 Okt 1922  Utica, Oneida County, New York, USA Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort  [37, 38
    Alter bei Heirat Er : 22 Jahre und 11 Monate - Sie : ~ 19 Jahre und 10 Monate. 
    Kinder 
     1. BRODT, Evelyn M
              geb. 2 Aug 1924, Rhode Island, USA Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort
              gest. nach 1985 (Alter > 62 Jahre)
     2. BRODT, Leonard Ernest
              geb. 15 Mrz 1926, Rhode Island, USA Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort
              gest. nach 1900
    NN(BRODT), Constance  verh. 1947
     3. BRODT, Robert Joseph
              geb. 24 Aug 1928, Greenville, Providence County, Rhode Island, USA Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort
              gest. 15 Dez 1994, Woonsocket, Providence County, Rhode Island, USA Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort (Alter 66 Jahre)
     4. BRODT, Howard
              geb. um 1930, Rhode Island, USA Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort
              gest. nach 1940 (Alter > 11 Jahre)
    Zuletzt bearbeitet am 30 Okt 2018 
    Familien-Kennung F11561  Familienblatt  |  Familientafel

  • Ereignis-Karte
    Link zu Google MapsGeburt - 30 Nov 1899 - Utica, Oneida County, New York, USA Link zu Google Earth
    Link zu Google MapsAufenthaltsort - - Sanford, York County, Maine, USA Link zu Google Earth
    Link zu Google MapsAufenthaltsort - Marital Status: Single; Relation to Head: Son - 1900 - Utica, Oneida County, New York, USA Link zu Google Earth
    Link zu Google MapsAufenthaltsort - Marital Status: Single; Relation to Head of House: Son - 1910 - Utica, Oneida County, New York, USA Link zu Google Earth
    Link zu Google MapsAufenthaltsort - Relation to Head of House: Son - 1 Jun 1915 - Utica, Oneida County, New York, USA Link zu Google Earth
    Link zu Google MapsAufenthaltsort - 1917 - Allegany County, New York, USA Link zu Google Earth
    Link zu Google MapsAufenthaltsort - Relation to Head: Son; Residence Marital Status: Single - 1920 - Utica, Oneida County, New York, USA Link zu Google Earth
    Link zu Google MapsEheschließung - 16 Okt 1922 - Utica, Oneida County, New York, USA Link zu Google Earth
    Link zu Google MapsAufenthaltsort - Relation to Head of House: Head - 1925 - Burrillville, Providence County, Rhode Island, USA Link zu Google Earth
    Link zu Google MapsAufenthaltsort - Marital Status: Married; Relation to Head: Head - 1930 - Smithfield, Providence County, Rhode Island, USA Link zu Google Earth
    Link zu Google MapsAufenthaltsort - 1934 - Providence County, Rhode Island, USA Link zu Google Earth
    Link zu Google MapsAufenthaltsort - Marital Status: Divorced; Relation to Head: Head - 1940 - Sanford, York County, Maine, USA Link zu Google Earth
    Link zu Google MapsBeerdigung - - North Smithfield, Providence County, Rhode Island, USA Link zu Google Earth
     = Link zu Google Earth 
    Pin-Bedeutungen  : Adresse       : Ortsteil       : Ort       : Region       : (Bundes-)Staat/-Land       : Land       : Nicht festgelegt

  • Quellen 
    1. [S0359] U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current.

    2. [S0360] 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Smithfield, Providence, Rhode Island; Page: 19A; Enumeration District: 0275; FHL microfilm: 2341907.

    3. [S0362] Web: Rhode Island, Historical Cemetery Commission Index, 1647-2008.

    4. [S0379] 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Utica Ward 9, Oneida, New York; Roll: T625_1245; Page: 8A; Enumeration District: 157.

    5. [S0380] New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Utica Ward 09; County: Oneida; Page: 05.

    6. [S0437] 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Utica Ward 9, Oneida, New York; Roll: T624_1053; Page: 5B; Enumeration District: 0138; FHL microfilm: 1375066.

    7. [S0438] 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Utica Ward 9, Oneida, New York; Roll: T625_1245; Page: 8A; Enumeration District: 157.

    8. [S0439] New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Utica Ward 09; County: Oneida; Page: 05.

    9. [S0440] Rhode Island, State Censuses, 1865-1935.

    10. [S0441] New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936.

    11. [S0442] U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007.

    12. [S0443] New York State, Birth Index, 1881-1942, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Birth Index.

    13. [S0444] U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: Allegany; Roll: 1711954.

    14. [S0445] New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index.

    15. [S0446] 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Sanford, York, Maine; Roll: m-t0627-01497; Page: 3B; Enumeration District: 16-72.

    16. [S0992] 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Utica Ward 14, Oneida, New York; Page: 15; Enumeration District: 0083; FHL microfilm: 1241134.

    17. [S1278] U.S. City Directories, 1822-1995.

    18. [S2749] 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Utica Ward 14, Oneida, New York; Page: 15; Enumeration District: 0083; FHL microfilm: 1241134.

    19. [S2750] 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Utica Ward 9, Oneida, New York; Roll: T624_1053; Page: 5B; Enumeration District: 0138; FHL microfilm: 1375066.

    20. [S2751] 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Utica Ward 9, Oneida, New York; Roll: T625_1245; Page: 8A; Enumeration District: 157.

    21. [S2752] New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Utica Ward 09; County: Oneida; Page: 05.

    22. [S2835] 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Utica Ward 14, Oneida, New York; Page: 15; Enumeration District: 0083; FHL microfilm: 1241134.

    23. [S2836] 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Utica Ward 9, Oneida, New York; Roll: T624_1053; Page: 5B; Enumeration District: 0138; FHL microfilm: 1375066.

    24. [S2837] 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Utica Ward 9, Oneida, New York; Roll: T625_1245; Page: 8A; Enumeration District: 157.

    25. [S2838] New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Utica Ward 09; County: Oneida; Page: 05.

    26. [S2839] Rhode Island, State Censuses, 1865-1935.

    27. [S2840] New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936.

    28. [S2841] U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current.

    29. [S2842] U.S. City Directories, 1822-1995.

    30. [S2843] U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007.

    31. [S2844] New York State, Birth Index, 1881-1942, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Birth Index.

    32. [S2845] U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: Allegany; Roll: 1711954.

    33. [S2846] New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index.

    34. [S2847] 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Smithfield, Providence, Rhode Island; Page: 19A; Enumeration District: 0275; FHL microfilm: 2341907.

    35. [S2848] 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Sanford, York, Maine; Roll: m-t0627-01497; Page: 3B; Enumeration District: 16-72.

    36. [S0378] 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Utica Ward 9, Oneida, New York; Roll: T624_1053; Page: 5B; Enumeration District: 0138; FHL microfilm: 1375066.

    37. [S0532] New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936.

    38. [S0533] New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index.